Résultats 1 - 71 de 71
Tableau avec des lignes rayées.
Trié par Collections propres à la région New York
Trier par Total
Testaments et documents de succession, New-York, États-Unis, 1659 à 1999 (en anglais)5 243 643
États généalogiques de New York, 1675-1920 (en anglais)797 866
Photos pour les impôts, New York, New York, États-Unis, 1940 (en anglais)682 866
Évaluations des taxes sur la propriété personnelle et la propriété réelle, New York, États-Unis, 1799 à 1804 (en anglais)452 016
Registres du Gouverneur concernant les internements de prisonniers, New York, États-Unis, 1842 à 1908 (en anglais)294 322
Archives de la Emigrant Savings Bank, New York, États-Unis, 1850 à 1883 (en anglais)284 268
Documentation de la reconstruction des recensements, États-Unis, 1660 à 1820 (en anglais)171 563
Index de lettres d’administration, comté de New York, de 1743 à 1875 (collection Barber) (en anglais)92 318
Registres d’admission de la prison de Sing Sing, New York, États-Unis, 1865 à 1939 (en anglais)78 507
Index de la Cour suprême et documents de la Cour de la Chancellerie, État de New York, 1648 à 1848 (en anglais)72 670
Ordres exécutifs pour les commutations, pardons, restaurations , clémences et répits, New York, États-Unis, 1845 à 1931 (en anglais)65 371
Libérations de prisonniers, New York, États-Unis, 1882 à 1915 (en anglais)51 220
Testaments et documents de succession, comté de New York, New York, États-Unis, 1658 à 1880 (NYSA) (en anglais)24 108
Sociétés demanderesses, New York, États-Unis, 1824 à 1911 (en anglais)20 399
Index des dossiers d’exclusion de chinois, New York, États-Unis, 1898 à 1943 (en anglais)18 564
Archives de l’établissement pénitentiaire de Great Meadow, New York, 1911 à 1933 (en anglais)17 311
Minutes of the Common Council of the city of New York, 1784-1831 (en anglais)14 732
Sélection de dossiers judiciaires du maire, New York, États-Unis, 1674 à 1860 (en anglais)9 144
Registres des mandats et des demandes d’extradition, État de New York, 1857 à 1938 (en anglais)7 575
Registres des admissions à la prison de Clinton, New York, États-Unis, 1851 à 1866 et 1926 à 1939 (en anglais)5 532
Prisonniers reçus à la Prison d’État de Newgate, New York, États-Unis, 1797 à 1810 (en anglais)5 198
Minutes of the Common Council of the city of New York, 1675-1776 : in eight volumes. (en anglais)3 766
Dossiers sélectionnés des débiteurs insolvables de AJHS, 1787 à 1861 (en anglais)3 497
The records of New Amsterdam from 1653 to 1674 anno Domini (en anglais)2 764
Versements pour les juifs Polonais, American Jewish Joint Distribution Committee (JDC ou le Joint), New York, États-Unis, 1915 à 1918 (en anglais)2 396
Journal of the Legislative Council of the colony of New-York (en anglais)2 105
Dossiers criminels de la Cour de circuit, États-Unis, 1790 à 1871 (en anglais)2 057
The Historic annals of southwestern New York (en anglais)2 033
Historical miscellany (en anglais)2 005
Comptes et inventaires de biens de successions, New York, États-Unis, 1666 à 1822 (en anglais)1 104
Western New York Land Transactions, 1825-1835 (en anglais)811
Long Island Source Records (en anglais)747
New York Wills, 1626-1836 (en anglais)673
Colonial charters, patents and grants to the communities comprising the city of New York (en anglais)665
Ventes des terres de Loyalistes, New York, États-Unis, 1762 à 1830 (en anglais)575
Index of wills for New York County, New York from 1851 to 1875, inclusive (en anglais)532
Index of wills for New York County (New York City) from 1662-1850 (en anglais)498
Western New York Land Transactions, 1804-1824 (en anglais)489
Official minutes of the New York Commercial Tercentary Commission (en anglais)475
Annals of Staten Island : from its discovery to the present time (en anglais)472
Historic Homes and Institutions and Genealogical and Family History of New York, Vol. II (en anglais)372
Harvard Club of New York City: constitution, by-laws, rules and list of officers and members. (en anglais)351
Historic Homes and Institutions and Genealogical and Family History of New York, Vol. IV (en anglais)340
Index of Wills Probated in Kings County, New York (en anglais)336
Minutes of the Town Courts of Newtown: 1656-1690 (en anglais)333
Historic Homes and Institutions and Genealogical and Family History of New York, Vol. I (en anglais)328
The Brooklyn Compendium (en anglais)324
Historic Homes and Institutions and Genealogical and Family History of New York, Vol. III (en anglais)302
The Thousand Islands of the River St. Lawrence (en anglais)302
English crown grants (en anglais)275
Documents and letters intended to illustrate the revolutionary incidents of Queens County (en anglais)262
Select patents of New York towns (en anglais)242
Landholders of Northeastern New York, 1739-1802 (en anglais)230
Long Island colonial patents (en anglais)198
Report of the Joint Committee on the Centennial Celebration of the Evacuation of New York by the British (en anglais)191
Record of real estate owned by the city of New York (en anglais)184
Abstracts of Van Voorhees family wills in the Surrogate's Office of New York County (en anglais)173
Wills of the Smith families of New York and Long Island, 1664-1794 (en anglais)166
Versements pour les juifs roumains, American Jewish Joint Distribution Committee (JDC ou le Joint), New York, États-Unis, 1917 à 1918 (en anglais)149
New York Alien Residents, 1825-1848 (en anglais)126
Records in the office of the county clerk at Jamaica, Long Island, New York (en anglais)122
Southold Connections (en anglais)118
List of persons who were taxed on seventeen thousand five hundred dollars and upwards in the city of New York (en anglais)99
Versements pour les juifs russes, American Jewish Joint Distribution Committee (JDC ou le Joint), New York, États-Unis, 1916 à 1917 (en anglais)98
Titles to land and land under water at Sea Gate, New York Harbor (en anglais)93
Miscellaneous material (en anglais)92
Abstract of wills probated in the Common Pleas Court (en anglais)71
Report on examination of personnel, methods of work and equipment of the Department of Street Cleaning, New York City (en anglais)47
Notes on the patroonships, manors and seigneuries in colonial times (en anglais)43
Minority report of the New York Charter Commission created by chapter 343 of the Laws of 1921, with proposed Home Rule Charter (en anglais)38
Save the City Hall and the City Hall Park (en anglais)15

Passer à toutes les collections liées à la région New York