Résultats 1 - 89 de 89
Tableau avec des lignes rayées.
Trié par Collections liées à la région New Hampshire
Trier par Total
Index de la Sécurité sociale, États-Unis, 1936 à 2007 (en anglais)133 418 498
Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO), États-Unis, 1970 à 2019 (en anglais)29 108 340
Listes d’estimation des impôts de l’IRS, États-Unis, 1862 à 1918 (en anglais)8 850 878
Atlas des propriétés des comtés des États-Unis, environ de 1860 à 1920 (en anglais)6 940 589
Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO), États-Unis, 1790 à 1909 (en anglais)3 577 054
Documents du Bureau des affranchis, États Unis, 1865 à 1878 (en anglais)3 235 082
Nominations des receveurs des postes des États-Unis, 1832 à 1971 (en anglais)1 514 110
Lettres reçues par le Bureau des affaires indiennes, États-Unis, 1824 à 1881 (en anglais)907 100
Documents de la banque des affranchis, États Unis, 1865 à 1874 (en anglais)685 322
Testaments et documents de succession, New Hampshire, États-Unis, 1643 à 1982 (en anglais)594 641
U.S., Union Provost Marshal Files of Individual Civilians, 1861-1866 (en anglais)502 957
Index des sujets des correspondances et dossiers du Service de l’immigration et de la naturalisation, États-Unis, 1903 à 1959 (en anglais)410 831
Listes des détenus des camps de concentration, États-Unis, 1944 à 1946 (en anglais)149 092
Pétitions du gouvernement, New Hampshire, États-Unis, 1700 à 1826 (en anglais)140 380
Listes des tribunaux, New Hampshire, États-Unis, 1800 à 1961 (en anglais)117 335
U.S., Union Provost Marshal Files of Two or More Civilians, 1861-1866 (en anglais)107 471
Fichiers de demande de pension et de concession de terre de la Guerre d’indépendance, États-Unis, 1800 à 1900 (en anglais)83 050
Documents associés à l’enrôlement des Cherokees de l’Est par Guion Miller, États-Unis, 1908 à 1910 (en anglais)79 496
Concessions de terre offertes aux anciens combattants, États-Unis, 1789 à 1858 (en anglais)76 126
Demandes privées de la Chambre des représentants, volume 1, États-Unis (en anglais)22 958
Registres de prisons, New Hampshire, États-Unis, 1812 à 1968 (en anglais)21 549
Demandes privées de la Chambre des représentants, volume 3, États-Unis (en anglais)20 768
Papiers d’Abraham Lincoln (en anglais)20 158
Dossiers du FBI relatif à l’identification des criminels décédés, États-Unis, 1971 à 1994 (en anglais)19 807
Actes et homologations des testaments, Mayflower, 1600 à 1850 (en anglais)18 601
Demandes privées de la Chambre des représentants, volume 2, États-Unis (en anglais)18 363
Traités indiens ratifiés, États-Unis, 1722 à 1869 (en anglais)10 048
États-Unis : noms juifs dans des fichiers du ministères des Affaires étrangères, 1910 à 1929 (en anglais)9 724
Atlas du monde et des États-Unis, 1822 à 1923 (en anglais)8 170
Liste ultime des esclaves et des biens, États-Unis, 1827 à 1828 (en anglais)4 931
Listes de l’émigration irlandaise, Irlande, 1833 à 1839 (en anglais)3 421
Décisions du Département de l’Intérieur des États-Unis concernant les demandes de pensions et de concessions de terres, 1886 à 1930 (en anglais)3 310
Documents de succession, New Hampshire, 1635 à 1753 (en anglais)3 242
Index de manuscrits de sol autochtone (en anglais)2 356
Fichiers des cartes d’identité des agents de la Prohibition, États-Unis, 1920 à 1925 (en anglais)1 772
Minutes of the court of Albany, Rensselaerswyck and Schenectady (en anglais)1 474
English Origins of New England Families, Second Series Vol. II (en anglais)1 046
English Origins of New England Families, Second Series Vol. III (en anglais)997
English Origins of New England Families, Vol. III (en anglais)883
English Origins of New England Families, Vol. II (en anglais)845
Minutes of the court of Fort Orange and Beverwyck (en anglais)652
Grâces accordées, New Hampshire, États-Unis, 1934 à 1937 (en anglais)649
Revolutionary War Bounty Land Grants (en anglais)636
Alleged frauds against certain Indian soldiers (en anglais)590
Concord town records, 1732-1820 (en anglais)581
The Mayflower Reader (en anglais)530
The Tichborne romance (en anglais)429
American Wills and Administrations (en anglais)423
Record of Indentures [1771-1773] (en anglais)362
American Wills Proved in London, 1611-1775 (en anglais)353
Family record of the Henderson and Whiddon families and their descendants (en anglais)316
English Origins of American Colonists (en anglais)294
The Pioneers of Maine and New Hampshire, 1623-1660 (en anglais)259
Fifty Puritan ancestors, 1628-1660 : genealogical notes, 1560-1900 (en anglais)230
American Colonists in English Records (en anglais)218
Collections for a genealogy of the noble families of Henzey, Tyttery, and Tyzack (De Hennezel, De Thiétry, and Du Thisac) (en anglais)218
Album des criminels, États-Unis, 1906 (en anglais)203
Records of the Halls of Wallingford and the Buckinghams of Milford (en anglais)166
American Data from the Records of the High Court of the Admiralty of Scotland, 1675-1800 (en anglais)160
La familia de Sor Juana Ines de la Cruz : documentos inéditos (en anglais)158
English Estates of American Colonists, 1700-1799 (en anglais)148
The Unton inventories, relating to Wadley and Faringdon, Co. Berks., in the years 1596 and 1620 (en anglais)142
A Calendar of the White Collection of Manuscripts in the Public Archives of Nova Scotia (en anglais)140
English Estates of American Settlers (en anglais)109
Carter (en anglais)109
Calendar of "Parsons" wills and administrations (Prerogative Court of Canterbury, &c., Somerset House, London) : from A.D. 1417 (en anglais)109
Early wills illustrating the ancestry of Harriot Coffin : with genealogical and biographical notes (en anglais)90
Family data relating to Fouts, Yount, Taylor & Hoovers (en anglais)87
To the descendants of Timothy Ingraham : information respecting the great Ingraham estate in the kingdom of Great Britain (en anglais)81
English Estates of American Colonists, 1610-1699 (en anglais)78
The Records of the Cranston family (en anglais)74
Division of Abington: closing argument of Hon. Ellis W. Morton before the Committee of the Legislature on Towns (en anglais)50
Abstracts of the wills of the Mather family (en anglais)39
Addenda to items of ancestry (en anglais)38
Dew wills and administrations : in the Prerogative Court of Canterbury (en anglais)37
Edward Washington and his kin (en anglais)37
Report of the executive board of the Friends' Association of Philadelphia and Its Vicinity, for the Relief of Colored Freedmen (en anglais)32
Extracts from British archives on the families of Halley, Hawley, Pyke, etc. (en anglais)32
A pedigree & genealogical notes, from wills, registers, and deeds of the highly distinguished family of Penn. (en anglais)29
Correspondance de l’American Protective League, États-Unis, 1917 à 1919 (en anglais)24
Will of Samuel St. John, 1844 (en anglais)23
The confession of faith, and catalogue of officers and members of the Congregational Church, in Rindge, N.H. : January 1848. (en anglais)21
Copies of public records re William Huddleston land grant (en anglais)20
Forbes family information (en anglais)20
Facts about the Carroll County Kearsarge Mountain of New Hampshire (en anglais)18
Halleian miscellany. (en anglais)16
Abstracts of wills and administration papers (en anglais)15
Botts family data (en anglais)13
A centennial law suit (en anglais)3

Passer à toutes les collections qui sont propres à la région New Hampshire