Résultats 1 - 100 de 127
Tableau avec des lignes rayées.
Trié par Collections liées à la région Maine
Trier par Total
Annuaires de ville, États-Unis, 1822 à 1995 (en anglais)1 385 585 010
Albums de souvenirs d’école, États-Unis, 1900 à 2016 (en anglais)881 226 611
Index des archives publiques, États-Unis, 1950 à 1993, Volume 1 (en anglais)418 676 051
Index des archives publiques, États-Unis, 1950 à 1993, Volume 2 (en anglais)402 455 524
Index des archives publiques, États-Unis, 1994 à 2019 (en anglais)330 831 836
Annuaires téléphoniques et d’adresses, États-Unis, 1993-2002 (en anglais)313 273 309
Catalogues d’écoles, États-Unis, 1754 à 1986 (en anglais)5 378 762
Registre officiel des États-Unis, 1863 à 1959 (en anglais)3 783 772
Annuaires du Royaume-Uni et des États-Unis, de 1680 à 1830 (en anglais)2 518 462
Listes des étudiants des établissements d’enseignement supérieur, 1763 à 1924 (en anglais)1 516 361
Index des pensions de retraite de la compagnie de chemins de fer, États-Unis, 1934 à 1987 (en anglais)1 514 828
Nominations des receveurs des postes des États-Unis, 1832 à 1971 (en anglais)1 514 110
Listes des étudiants, États-Unis, 1821 à 1923 (en anglais)645 940
Annuaires des anciens étudiants des universités Quaker, États-Unis, 1911 à 1940 (en anglais)521 947
Web : Accidents de mines, États-Unis, 1839 à 2006 (en anglais)520 498
Fiches du Cadet Nurse Corps pendant la Seconde Guerre Mondiale, États-Unis, 1942 à 1948 (en anglais)390 020
Sélection de registres de l’Église méthodiste unie, Nouvelle-Angleterre, 1787 à 1922 (en anglais)374 894
Encyclopédie de la Généalogie des Quakers américains, Vol I–VI, États-Unis, 1600 à 1900 (en anglais)356 712
Registre national des professionnels scientifiques et techniques, États-Unis, 1921 à 1970 (en anglais)320 834
Maine, U.S., City Directories (en anglais)170 315
Questionnaires de Baseball, États-Unis, 1945 à 2005 (en anglais)154 715
Directory of Deceased American Physicians, 1804-1929 (en anglais)148 655
Documents de la migration des Mormons, États-Unis, 1840 à 1932 (en anglais)143 658
Comptes rendus des assemblées annuelles Quaker, États-Unis, 1808 à 1930 (en anglais)116 253
Registre de l’Église SDJ, Appartenance à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1830 à 1848 (en anglais)104 231
Registres des membres de Sons of Norway, Minnesota, États-Unis, 1737 à 1970 (en anglais)90 584
Index des nécrologies Quaker, États-Unis, 1822 à 2012 (en anglais)79 196
Fiches de service des préposés aux hôpitaux, matrones et infirmières, États-Unis, 1861 à 1865 (en anglais)73 588
Portland, Maine répertoires de ville, 1889-91 (en anglais)65 403
Substitut de recensement d’annuaires de ville, 1890 (en anglais)63 405
Pages commémoratives publiées pour les Quakers, États-Unis et Royaume-Uni, 1818 à 1919 (en anglais)55 135
Annuaires de ville, Bangor, Maine, États-Unis, 1882 à 1892 (en anglais)52 580
Généalogies des Quakers, États-Unis, 1893 à 2003 (en anglais)31 254
Web : Index des certificats de protection des matelots, États-Unis, 1796 à 1871 (en anglais)29 384
Lewiston, Androscoggin County, Maine, répertoires de ville, 1908 (en anglais)26 324
Premiers membres de l’Église réorganisée de Jésus-Christ des saints des derniers jours (en anglais)25 973
Compilation de documents de plusieurs sociétés généalogiques, États-Unis, 1875 à 2010 (en anglais)22 086
Publications d’histoires de familles Quaker, États-Unis (en anglais)17 950
Joueurs professionnels de Baseball, de 1876 à 2004 (en anglais)13 622
Annuaire biographique du Congrès des États-Unis, 1774 à 2005 (en anglais)12 184
U.S., Sons of the American Revolution, 1783-1902 (en anglais)10 909
Index des forgerons et métiers connexes, 1720 à 1940 (en anglais)9 916
Membres de l’American Protective League, États-Unis, 1917 à 1919 (en anglais)8 804
Annuaire ministériel presbytérien, 1898 (en anglais)8 484
Registres missionnaires baptistes et cartes de navigation, Géorgie, États-Unis, 1814 à 1970 (en anglais)8 068
Biddeford, Maine répertoires de ville, 1890-91 (en anglais)7 395
Annuaires du Motion Picture Studio, 1919 et 1921 (en anglais)6 707
Annuaire, région d’Augusta, Maine, États-Unis, 1882 (en anglais)6 245
Annuaire du clergé de l’Église épiscopalienne protestante, États-Unis, 1898 (en anglais)5 054
Annuaire de Lewiston et Auburn, comté d’Androscoggin, Maine, 1860 (en anglais)4 009
Index des assemblées mensuelles Quaker, États-Unis et Canada, 1671 à 2010 (en anglais)2 087
Fichiers des cartes d’identité des agents de la Prohibition, États-Unis, 1920 à 1925 (en anglais)1 772
Dossiers des infirmiers et infirmières de la Croix-Rouge américaine pendant la Première Guerre Mondiale, États-Unis, 1916 à 1959 (en anglais)1 491
Williams' Cincinnati directory (en anglais)1 334
Guide pratique des auteurs américains, 1907 (en anglais)930
Harvard alumni directory, 1919 (en anglais)803
Obituary record of the graduates of Bowdoin College and the Medical School of Maine for the decade ending 1 June 1909 (en anglais)510
Memorials of the introduction of Methodism into the eastern states (en anglais)487
An apology for African Methodism (en anglais)475
A Brief History of the Lutheran Church in America (en anglais)467
The New-York annual register for the year of our Lord 1834 (en anglais)446
Index des noms de famille dans les archives des Quakers, États-Unis (en anglais)444
Highways and hedges, or, Fifty years of western Methodism (en anglais)396
Friends of a half century : fifty memorials with portraits of members of the Society of Friends, 1840-1890 (en anglais)389
The Maine register and business directory for the year 1856 (en anglais)360
Directory of the cities of Augusta, Hallowell and Gardiner for 1882 (en anglais)338
A history of the German Congregational churches in the United States (en anglais)328
The town register, East Livermore, Livermore, Jay, 1909 (en anglais)302
The Colonial Clergy and the Colonial Churches of New England (en anglais)281
A History of the Wedgwood Family (en anglais)272
The Town register, Farmington, Wilton, Chesterville, New Sharon (en anglais)271
The town register, Wayne, Wales, Monmouth, Leeds, Greene : 1905 (en anglais)255
Twenty years at Pemaquid : sketches of its history and its remains, ancient and modern (en anglais)253
The town register, Islesboro, Castine, Penobscot, Brooksville, 1906 (en anglais)247
The town register, Gorham and Buxton, 1905 (en anglais)233
Scenes in a vestry : being an account of the late controversy in the South Parish Congregational Church in Augusta (en anglais)232
The Lewiston and Auburn directory : containing the names of the inhabitants, their occupation and places of business, &c., the (en anglais)217
Founding and organization of the Daughters of the American Revolution and Daughters of the Revolution (en anglais)206
History of the State Normal School, Farmington, Maine : with sketches of the teachers and graduates (en anglais)203
Cyclopaedia of African Methodism (en anglais)198
Family notes and reminiscences (en anglais)191
Directory of churches and religious organizations in Maine (en anglais)171
The Town Register, Otisfield, Harrison, Naples and Sebago: 1906 (en anglais)169
Peirce's Colonial Lists (en anglais)159
Resident and business directory of the town of Brunswick and Topsham village, with maps (en anglais)157
Christ Church, Gardiner, Maine : antecedents and history (en anglais)156
Arrivées des Quakers à Philadelphie, 1682 à 1750 (en anglais)137
Souvenir and directory of the St. Paul Presbyterian Church of Philadelphia (en anglais)136
Register of the St. Albans Presbyterian Church : organized August 22, 1868 : Seventh Avenue and E Street, St. Albans, W. Va. (en anglais)129
A centennial discourse delivered to the First Congregational Church and Society in Leominster, September 24, 1843 (en anglais)114
The Webster, West Gardiner, Litchfield, and Monmouth register, 1909 (en anglais)104
Remembering the days of old, or, The Puritans and their descendants (en anglais)97
History of the Park Ridge schools, 1808 to 1938 (en anglais)96
Appleton register, 1903 : containing history, date of birth of all residents, deaths : business directory (en anglais)95
Historical sketch of the Congregational church and parish of Canton Center, Conn. (en anglais)94
First annual gathering of the Clan MacLean Association of North America : held in the city of Chicago, June 12-16, 1893 (en anglais)83
The Milbridge register, 1905 (en anglais)79
The centennial of the Cumberland Association of Congregational Ministers (en anglais)78
Historical sketch and principles and regulations, with a list of former and present members of the First Congregational Church, Farmington, Maine (en anglais)78
Celebration of the two hundred and fiftieth anniversary of the landing of Samuel Packard in this country, August 10, 1638 (en anglais)73

Passer à toutes les collections qui sont propres à la région Maine